USA
PA
McKean County
Lafayette
Potter, Albert Carollton  b. 1900, d. 1943
Potter, George Edward  b. 1897, d. 1968
Potter, Hiram Harold  b. 1869, d. 1925
Shafer, Martha A.  b. 1880, d. 1912
Lewis Run
Potter, Albert Carollton  b. 1900, d. 1943
Potter, Hiram Harold  b. 1869, d. 1925
Potter, Hiram Harold Jr.  b. 1904, d. 1958
Shafer, Martha A.  b. 1880, d. 1912
Mount Jewett
Youngberg, Sadie Elizabeth  b. 1895, d. 1957
Mercer County
Clarks Mills
Holcomb, Dorothy I.  b. 1917, d. 1997
Lombard, David Lyle  b. 1948, d. 1997
Lombard, David Lyle  b. 1948, d. 1997
Farrell
White, Joseph  b. 1904, d. 1977
Greenville
Brittain, Mildred M.  b. 1885, d. 1977
Kennedy, Charles Frank  b. 1852, d. 1939
Grove City
Craig, Mary A.  b. 1846, d. 1927
Rich, Phebe Margaret  b. 1843, d. 1916
Pardoe
Cornelius, Alice Mary  b. 1880, d. 1951
West Middlesex
Zigler, Margaret Jane  b. 1829, d. 1882
Mifflin County
Bousom, John Gus (Dr.)  b. 1898, d. 1970
Brown
Houser, Charles Ammon Sr.  b. 1908, d. 1965
Lewiston
Noble, Margaret Hamilton  b. 1917, d. 1996
Lewistown
Carper, Josephine Alfarata  b. 1925, d. 1999
Cupples, Martin Louis Sr.  b. 1848, d. 1928
Houser, Charles Ammon Sr.  b. 1908, d. 1965
Martin, Bernice Irene  b. 1913, d. 1987
Noble, Margaret Hamilton  b. 1917, d. 1996
Noel, Catherine Clothilde  b. 1857, d. 1930
Noel, Charles M.  b. 1898, d. 1956
Noel, John James Jr.  b. 1896, d. 1918
Noel, Lena Rosalia  b. 1866, d. 1953
Noel, Ralph Joseph  b. 1892, d. 1957
Noel, William Leo  b. 1894, d. 1954
O'Hara, Francis C. (Rev.)  b. 1909, d. 1986
O'Hara, Robert  b. 1868, d. 1916
Sutton, Kathryn May  b. 1898, d. 1962
Wertz, Thomas Andrew  b. 1896, d. 1980
Wayne
Potter, Miles Isaac  b. 1865, d. 1935
Monroe County
Cresco
Kozatiwitz, Alice M.  b. 1940, d. 2021
East Stroudsburg
Kresge, Sebastian Spering  b. 1867, d. 1966
Mountainhome
Kresge, Sebastian Spering  b. 1867, d. 1966
Zitz, Clara Katherine  b. 1894, d. 1981
Stroudsburg
Harvey, Anna Emma  b. 1879, d. 1968
Montgomery County
Warr, Dorothy Florence  b. 1917, d. 2012
Wishwanick, William Nick  b. 1925, d. 2006
Wolford, John  b. 1754, d. 1839
Work, Alice Elwanda  b. 1932, d. 1972
Abington
Bresser, David Michael  b. 1971, d. 1971
Bresser, Johannes Heinrich Frederikus  b. 1937, d. 2014
Hartzell, Richard Graham Jr.  b. 1965, d. 1977
Rose, Joan Madeline  b. 1932, d. 1994
Sutton, Martha Ann  b. 1947, d. 2001
Warr, Dorothy Florence  b. 1917, d. 2012
Ambler
Bonsell, Milton Edward  b. 1925, d. 2007
Sutton, Martha Ann  b. 1947, d. 2001
Tomlinson, James Edward  b. 1935, d. 1979
Fort Washington
Bonsell, Milton Edward  b. 1925, d. 2007
Bonsell, Stephen  b. 1959, d. 2007
Tomlinson, Elizabeth Genevieve  b. 1928, d. 1973
Tomlinson, James Edward  b. 1935, d. 1979
Glenside
Lombard, Irma P.  b. 1908, d. 1984
Lombard, Irma P.  b. 1908, d. 1984
Millham, Franklin Bechtel  b. 1907, d. 1993
Sutton, Martha Ann  b. 1947, d. 2001
Horsham
Jenkintown
Sutton, Wilfred Paul  b. 1915, d. 1982
Warr, Dorothy Florence  b. 1917, d. 2012
Lansdale
Frain, Anne Margaret  b. 1920, d. 1992
Lower Providence
Dyer, Dinah Hinckley  b. 1825, d. 1901
Lombard, Mary Isabel  b. 1858, d. 1900
Lombard, Mary Isabel  b. 1858, d. 1900
Pottstown
Mercer, Chester Lynwood  b. 1918, d. 2004
Prospectville
Sutton, Wilfred Paul  b. 1915, d. 1982
Royersford
Duranso, Earl Reynolds  b. 1894, d. 1982
Schwenksville
Showalter, Virginia Lea  b. 1925, d. 2021
Telford
Corrick, Olive Bessie  b. 1879, d. 1972
Montour County
Lumbard, Joseph Asher Jr.  b. 1940, d. 2003
Stahl, Kathryn Lorraine  b. 1950, d. 2019
Danville
Carper, Josephine Alfarata  b. 1925, d. 1999
Flowers, William Harold  b. 1923, d. 1984
Lumbard, Barry Lee  b. 1947, d. 2008
Lumbard, Joseph Asher Jr.  b. 1940, d. 2003
Lumbard, Kellar Loreno  b. 1896, d. 1984
McLain, Miles Samuel  b. 1904, d. 1974
Noel, Lena Rosalia  b. 1866, d. 1953
Seiger, Paul Richard (Imschweiler)  b. 1937, d. 1985
Smith, Lois Jane  b. 1916, d. 2012
Sulouff, Thomas Wade  b. 1957, d. 1957
Northampton County
Bethlehem
Custeau, Emile Michele  b. 1907, d. 1991
Lombard, Helen Mildred  b. 1908, d. 1999
Lombard, Helen Mildred  b. 1908, d. 1999
Easton
Rourke, John Nugent  b. 1900, d. 1963
Smith, Marion Irene  b. 1902, d. 1992
Hellertown
Machain, Mercedes A.  b. 1938, d. 2018
Northumberland County
Conrad, June Marie  b. 1930, d. 1997
Dailey, Florence E.  b. 1926, d. 1999
Flowers, William Harold  b. 1923, d. 1984
Gibney, Irene  b. 1898, d. before 1972
Haddock, Josephine  b. 1909, d. 2009
Jarrett, Hattie Leota  b. 1888, d. 1970
Jorich, Margaret Mildred  b. 1924, d. 2002
Persing, Merlin Eugene  b. 1926, d. 1985
Smith, Jay Donald  b. 1899, d. 1939
Swartzlander, Sydney Cleveland  b. 1884, d. 1955
Walter, Francis William  b. 1927, d. 1991
Bear Gap
Haldeman, Charles Leroy  b. 1888, d. 1963
Coal
Haddock, Josephine  b. 1909, d. 2009
Smith, (?)  b. 1926, d. 1927
Elysburg
Persing, Merlin Eugene  b. 1926, d. 1985
Milton
Boyer, Marion Carl Sr.  b. 1895, d. 1975
Hoffman, Marshall Gates  b. 1892, d. 1942
Montandon
Boyer, Marion Carl Sr.  b. 1895, d. 1975
Lumbard, Helen May  b. 1918, d. 2012
Northumberland
Faiazzi, Michael J.  b. 1919, d. 2006
Gingrich, Pearl Amber  b. 1914, d. 1987
Lumbard, Harriet M.  b. circa 1921, d. 2010
Sulouff, Carl Emery  b. 1952, d. 2020
Paxinos
Persing, Merlin Eugene  b. 1926, d. 1985
Potts Grove
Lumbard, Helen May  b. 1918, d. 2012
Rural Point
Lumbard, Joseph Asher  b. 1911, d. 1954
Shamokin
Briel, Arlene Larue  b. 1939, d. 2000
Haddock, Josephine  b. 1909, d. 2009
Phillips, Michael Aubrey  b. 1907, d. 1986
Smith, Jay Donald  b. 1899, d. 1939
Sunbury
Cloud, Laura M.  b. 1875, d. circa 1911
Conrad, June Marie  b. 1930, d. 1997
Cromley, Mary Elizabeth  b. 1893, d. 1957
Culp, Woodrow Lee  b. 1931, d. 2009
Dailey, Florence E.  b. 1926, d. 1999
Delaney, Margaret Mary  b. 1933, d. 2003
Duck, Henry J.  b. 1855, d. 1928
Faiazzi, Michael J.  b. 1919, d. 2006
Flowers, William Harold  b. 1923, d. 1984
Furr, Charles Bruce  b. 1894, d. 1961
Haldeman, Charles Leroy  b. 1888, d. 1963
Huff, Katherine Della  b. 1894, d. 1972
Jarrett, Hattie Leota  b. 1888, d. 1970
Jones, Esther Beatrice  b. 1889, d. circa 1916
Jorich, Margaret Mildred  b. 1924, d. 2002
Lumbard, Albert Richard  b. 1937, d. 2007
Lumbard, Anna May  b. 1869, d. 1929
Lumbard, Barry Lee  b. 1947, d. 2008
Lumbard, Harriet M.  b. circa 1921, d. 2010
Lumbard, Janet Elizabeth  b. 1939, d. 2006
Lumbard, Joseph Asher Jr.  b. 1940, d. 2003
Lumbard, Robert Meade  b. 1934, d. 1995
Lumbard, Sarah Ethel  b. 1879, d. 1931
Lumbard, William Douglas  b. 1937, d. 1940
McLain, Alfred Lumbard  b. 1895, d. 1946
Ridge, Nina Frances  b. 1918, d. 1990
Shafer, John E.  b. 1868, d. 1944
Smith, Ethel Jean  b. 1906, d. 1914
Smith, Eugenia L.  b. 1918, d. 1972
Smith, Helen Lumbard  b. 1900, d. 1986
Smith, Lois Jane  b. 1916, d. 2012
Smith, Murray Walter  b. 1876, d. 1948
Smith, Richard Walter  b. 1908, d. 1986
Snyder, Marion McKay  b. 1901, d. 1985
Swartzlander, Sydney Cleveland  b. 1884, d. 1955
Walter, Francis William  b. 1927, d. 1991
Warr, Dorothy Florence  b. 1917, d. 2012
West Chillisquaque
Cromley, Mary Elizabeth  b. 1893, d. 1957
Nietz, Miriam Elsie  b. 1902, d. 1934
Perry County
Duncannon
McCullough, Chester Leon  b. 1918, d. 2000
Liverpool
Bousom, George Francis  b. 1869, d. 1963
Newport
Fickes, Barbara Elizabeth  b. 1923, d. 2004
Shryock, Richard Wallace  b. 1927, d. 2003
Philadelphia County
Christie, Inez Grenier  b. 1879, d. 1951
De Gralla, Harriet J.  b. 1885, d. 1954
Schaffer, Charles Richard  b. 1882, d. 1934
Germantown
Chapman, John Ward  b. 1916, d. 1990
Frink, Ellis Alexander  b. 1862, d. 1951
Philadelphia
Barclay, William Lyttleton Jr.  b. 1899, d. 1994
Bowden, Helen Gertrude  b. 1920, d. 2005
Brodhead, Claude Ross  b. circa 1850
Burr, Jessie Elva  b. 1880, d. 1924
Cauffman, Rachel  b. 1784, d. 1855
Collins, Eben H.  b. 1873, d. 1942
Cox, Paul Bruce  b. 1900, d. 1960
De Gralla, Harriet J.  b. 1885, d. 1954
Dempsey, William James  b. 1893, d. 1971
Faust, Kathleen Lee  b. 1951, d. 1975
Fechter, Irwin J.  b. 1845, d. 1903
Flint, Douglas A.  b. 1861, d. 1928
Foulks, Helen Joan  b. 1914, d. 1979
Frankllin, William Edmund  b. 1866, d. 1918
Hanlon, Edward Francis  b. 1919, d. 1979
Harding, Stephen Atwood Jr.  b. 1828, d. 1878
Hartzell, Richard Graham Jr.  b. 1965, d. 1977
Haskins, Carlotta Laura  b. 1873, d. 1933
Hempstead, Harry Newton  b. 1868, d. 1938
Hewitt, Charles Albert  b. circa 1829, d. 1874
Hoffman, Marshall Gates  b. 1892, d. 1942
Hopkins, Edward  b. 1794, d. 1869
Hudson, Max Burdette  b. 1892, d. 1959
Jackson, John F.  b. circa 1846, d. circa 1888
Johnson, Clarissa Augusta  b. circa 1845, d. 1877
Kelly, Mary Ella  b. circa 1865
Laird, Ruth Anna  b. 1888, d. 1943
Lambord, William Henry  b. 1838, d. between 1882 and 1900
Lara, Edward Morris  b. 1881, d. 1948
Lauer, Leo Robert  b. 1902, d. 1969
Leeds, Edward Fowler Sr.  b. 1868, d. 1908
Lockerman, Eliza Ann  b. circa 1843, d. 1881
Lombard, Alonzo A.  b. 1843, d. 1864
Lombard, Anna Jones  b. 1826, d. 1897
Lombard, Cora Belle  b. 1880, d. 1934
Lombard, Edward Shirley  b. 1851, d. 1916
Lombard, Emily Holmes  b. 1903, d. 1993
Lombard, Emily Melville  b. 1828, d. 1885
Lombard, Eudora Josephine  b. 1853, d. 1928
Lombard, Frances Young  b. 1854, d. 1936
Lombard, John Adams  b. 1834, d. 1893
Lombard, Mary Isabel  b. 1858, d. 1900
Lombard, May Belle  b. circa 1867, d. 1879
Lombard, Ola Lillian  b. 1889, d. 1980
Lombard, Roswell  b. 1821, d. 1890
Lombard, Alonzo A.  b. 1843, d. 1864
Lombard, Anna Jones  b. 1826, d. 1897
Lumbard, Anna Kathleen  b. 1901, d. 2007
Lombard, Cora Belle  b. 1880, d. 1934
Lombard, Edward Shirley  b. 1851, d. 1916
Lombard, Emily Holmes  b. 1903, d. 1993
Lombard, Emily Melville  b. 1828, d. 1885
Lombard, Eudora Josephine  b. 1853, d. 1928
Lombard, Frances Young  b. 1854, d. 1936
Lumbard, George Washington  b. 1905, d. 1983
Lumbard, Horatio Gates  b. 1822, d. 1892
Lombard, John Adams  b. 1834, d. 1893
Lumbard, Margaret Ruth  b. 1933, d. 2017
Lombard, Mary Isabel  b. 1858, d. 1900
Lombard, May Belle  b. circa 1867, d. 1879
Lombard, Ola Lillian  b. 1889, d. 1980
Lumbard, Robert Hill  b. 1929, d. 1987
Lombard, Roswell  b. 1821, d. 1890
Lambord, William Henry  b. 1838, d. between 1882 and 1900
Maier, Bernice Dorothy  b. 1904, d. 2001
McBrearty, John J.  b. 1897, d. 1969
McDermott, Annie Jane  b. 1845, d. 1901
Mecka, Amelia Emily  b. 1912, d. 2009
Moorehouse, Franklin Colfax  b. 1872, d. 1950
Noel, Mary  b. 1851, d. 1903
O'Reilly, Margaret Mary  b. 1908, d. 1968
Patterson, Charles Henry  b. 1851, d. 1898
Patterson, Edward Francis  b. 1873, d. 1874
Patterson, Henry Stanley  b. 1877, d. 1943
Patterson, Henry Stanley Jr.  b. 1915, d. 1978
Patterson, Joanna M. Jane  b. 1813, d. 1897
Patterson, Johanna  b. 1845, d. 1853
Patterson, John  b. 1779, d. 1819
Patterson, John Austin Saunders  b. 1843, d. 1903
Patterson, Joseph  b. 1883, d. 1886
Patterson, Mary C.  b. 1853
Patterson, Maurice P.  b. 1848, d. 1909
Patterson, Thomas Stanley  b. 1910, d. 1985
Patterson, Walter Augustin Edward  b. 1817, d. 1864
Patterson, Walter Francis  b. 1846, d. 1919
Patterson, Walter Francis Jr.  b. 1874, d. 1953
Pie, Ralph Mackenzie  b. 1893, d. 1965
Reublinger, Charles Richard  b. 1915, d. 1999
Reustle, Charles Herman  b. 1920, d. 1976
Reynolds, Harry J.  b. circa 1883
Rond, Mabel Lynne  b. 1883, d. 1939
Rose, Joan Madeline  b. 1932, d. 1994
Rowley, Salmon Bostwick  b. 1827, d. 1905
Sargent, Cynthia A.  b. 1855, d. 1940
Saul, Henry George  b. 1849, d. 1937
Saunders, Elizabeth Eliza  b. 1816, d. 1854
Schaffer, Charles Richard  b. 1882, d. 1934
Sharp, Thelma  b. 1917, d. 1982
Smith, Agnes Helena  b. 1886
Steward, Helen Stanley  b. 1852, d. 1927
Thursby, Josephine Matilda Leland Kalbfleisch  b. 1866, d. 1939
Town, Lucy Elizabeth M.  b. circa 1849, d. 1891
Wakeman, John James  b. 1930, d. 2005
Wallace, Warren Lee (Dr.)  b. 1870, d. 1940
Wise, Sallie Ann  b. circa 1850, d. 1888
Wishwanick, William Nick  b. 1925, d. 2006
Phliadelphia
Rose, Joan Madeline  b. 1932, d. 1994
Wakeman, John James  b. 1930, d. 2005
Spring Garden
Patterson, Johanna  b. 1845, d. 1853
Patterson, John Austin Saunders  b. 1843, d. 1903
Patterson, Maurice P.  b. 1848, d. 1909
Patterson, Walter Augustin Edward  b. 1817, d. 1864
Patterson, Walter Francis  b. 1846, d. 1919
Saunders, Elizabeth Eliza  b. 1816, d. 1854
Potter County
Austin
Johnson, Waldamar Ogden  b. 1893, d. 1966
Coudersport
Groves, Robert Lenox  b. 1885, d. 1962
Germania
Zepp, Helen Elizabeth  b. 1912, d. 2004
Schuylkill County
Coaldale
Brimmer, Chester Benjamin  b. 1909, d. 1981
Donaldson
Hegins
Schrope, Katie Fydeela  b. 1907, d. 1962
Orwigsburg
Hartzell, Richard Graham  b. 1938, d. 2021
Snyder County
Duck, Jacob  b. 1822, d. 1862
Lumbard, Harriet M.  b. circa 1921, d. 2010
Staum, Mary Ann  b. 1827, d. 1900
Swartzlander, Sydney Cleveland  b. 1884, d. 1955
Kreamer
Smith, Murray Walter  b. 1876, d. 1948
McClure
Mumma, Mabel Irene  b. 1902, d. 1995
Middleburg
Dietrich, Harriet M.  b. 1906, d. 1995
Huff, Katherine Della  b. 1894, d. 1972
Lumbard, George Meade  b. 1874, d. 1925
Lumbard, Kellar Loreno  b. 1896, d. 1984
Lumbard, Lucy Irene  b. 1867, d. 1937
McLain, Alfred Lumbard  b. 1895, d. 1946
McLain, Delbert Eugene  b. 1899, d. 1977
McLain, Miles Samuel  b. 1904, d. 1974
McLain, Paul Luther  b. 1897, d. 1906
Potter, Joseph Lumbard (Dr.)  b. 1893, d. 1958
Potter, Miles Isaac  b. 1865, d. 1935
Simms, Beulah Laverda  b. 1882, d. 1968
Penn
Duck, Jacob  b. 1822, d. 1862
Jarrett, Hattie Leota  b. 1888, d. 1970
Lumbard, George Meade  b. 1874, d. 1925
Staum, Mary Ann  b. 1827, d. 1900
Selinsgrove
Bousom, George Francis  b. 1869, d. 1963
Carson, Stewart William  b. 1906, d. 1968
Conrad, June Marie  b. 1930, d. 1997
Duck, (?)  b. circa 1853, d. circa 1853
Duck, Edward E.  b. circa 1862, d. 1940
Duck, Emma L.  b. circa 1848, d. before 1860
Duck, Henry J.  b. 1855, d. 1928
Duck, Mary  b. circa 1857, d. before 1900
Duck, William Hall  b. 1851, d. 1920
Jarrett, Hattie Leota  b. 1888, d. 1970
Keller, Anna Laura  b. 1875, d. 1908
Lumbard, Albert Meade  b. 1912, d. 1975
Lumbard, Anna Kathleen  b. 1901, d. 2007
Lumbard, Anna May  b. 1869, d. 1929
Lumbard, George Meade  b. 1874, d. 1925
Lumbard, George Washington  b. 1905, d. 1983
Lumbard, Joseph Asher  b. 1844, d. 1915
Lumbard, Joseph Asher  b. 1911, d. 1954
Lumbard, Kellar Loreno  b. 1896, d. 1984
Lumbard, Lucy Irene  b. 1867, d. 1937
Lumbard, Maude Vernon  b. 1871, d. 1951
Lumbard, Paul Lincoln  b. 1923, d. 1990
Lumbard, Robert Kurtz  b. 1907, d. 1911
Lumbard, Ruth Laverda  b. 1917, d. 1922
Lumbard, Sarah Ethel  b. 1879, d. 1931
McLain, Delbert Eugene  b. 1860, d. 1909
McLain, Leah Kathryn  b. 1908, d. 1978
Potter, Miles Isaac  b. 1865, d. 1935
Scharf, Sarah Ethel  b. 1845, d. 1924
Smith, Ethel Jean  b. 1906, d. 1914
Smith, Helen Lumbard  b. 1900, d. 1986
Smith, Jay Donald  b. 1899, d. 1939
Smith, Murray Walter  b. 1876, d. 1948
Staum, Mary Ann  b. 1827, d. 1900
Swartzlander, Sydney Cleveland  b. 1884, d. 1955
Somerset County
Chase, Lovina  b. 1807, d. 1855
Feather, Eva Catherine  b. 1798, d. 1854
Hewitt, Sarah  b. 1792, d. 1854
Addison
O'Hanlon, Richard Martin  b. 1927, d. 2009
Elk Lick
Wilt, Priscilla Jane  b. 1933, d. 1998
Somerset
Criste, Dorothy Frances  b. 1957, d. 2022
Ellenberger, Margaret  b. 1825, d. 1911
McMullen, Jane  b. 1798, d. 1880
Turkeyfoot
Hartzell, Jacob  b. 1822, d. 1897
Wellersburg
Bender, Weldon Daniel  b. 1914, d. 1973
Showalter, Mae  b. 1912, d. 1965
Susquehanna County
Forest City
Petokas, Peter Francis  b. 1919, d. 1993
Hop Bottom
Whitney, Streeter  b. 1813, d. 1886
Tioga County
Allen, Edgar David  b. 1838, d. 1904
Decker, Mary E.  b. circa 1848, d. 1916
Lumbard, Samuel L.  b. 1850, d. 1904
Blossburg
Hyland, Alice M.  b. 1887, d. 1946
Lumbard, James Monroe  b. 1871, d. 1932
Liberty
McLain, Delbert Eugene  b. 1860, d. 1909
McLain, Joseph Charles  b. 1902, d. 1982
McLain, Leah Kathryn  b. 1908, d. 1978
McLain, Miles Samuel  b. 1904, d. 1974
McLain, Paul Luther  b. 1897, d. 1906
Wellsboro
Dickson, William Henry  b. 1827, d. 1888
Union County
Duck, Emma L.  b. circa 1848, d. before 1860
Goodall, Malcolm Leon  b. 1912, d. 2007
Lumbard, Helen May  b. 1918, d. 2012
Lewisburg
Cromley, Mary Elizabeth  b. 1893, d. 1957
Furr, Charles Bruce  b. 1894, d. 1961
Gehrer, Michael Wayne  b. 1952, d. 2010
Gingrich, Pearl Amber  b. 1914, d. 1987
Goodall, Malcolm Leon  b. 1912, d. 2007
Lumbard, Helen May  b. 1918, d. 2012
Smith, Helen Lumbard  b. 1900, d. 1986
Sulouff, Carl Emery  b. 1952, d. 2020
New Berlin
Boyer, Marion Carl Sr.  b. 1895, d. 1975
White Deer
Huff, Katherine Della  b. 1894, d. 1972
Venango County
Cornplanter
Long, Paul Henry  b. 1842, d. 1927
Potter, Sarah Maranda  b. 1843, d. 1876
Franklin
Carter, Lewis Wesley  b. 1876, d. 1939
Cornelius, Alice Mary  b. 1880, d. 1951
Galloway
Carter, Lewis Wesley  b. 1876, d. 1939
Oakland
Carter, Lewis Wesley  b. 1876, d. 1939
Oil City
Lumbert, Mary P.  b. 1867, d. 1929
Lumbert, Mary P.  b. 1867, d. 1929
Paine, Isabelle Marie  b. 1908, d. 1983
Washington County
Moore, George W. (Rev.)  b. 1828, d. 1900
O'Hanlon, Joseph A.  b. 1910, d. 1976
Sherry, Louise Genevieve  b. 1909, d. 2006
Summers, Doris Catherine  b. 1912, d. 2003